Regulation of proper gene expression is important for cellular and organismal survival, maintenance, and growth. Abnormal gene expression, even for a single critical gene, can thwart cellular integrity and normal physiology to cause diseases, aging, and death. Therefore, gene expression profiling serves as a powerful tool to understand the pathology of diseases and to cure them. In this study, the difference in gene expression in Flammulina velutipes was compared between the wild type (WT) mushroom and the mutant one with clogging phenomenon. Differentially expressed transcripts were screened to identify the candidate genes responsible for the mutant phenotype using the DNA microarray analysis. A total of 88 genes including 60 upregulated and 28 downregulated genes were validated using the real-time quantitative PCR analysis. In addition, proteomic differences between the WT and mutant mushroom were analyzed using two-dimensional gel electrophoresis and matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight (MALDI-TOF). Interestingly, the genes identified by these genomic and proteomic analyses were involved in stress response, translation, and energy/sugar metabolism, including HSP70, elongation factor 2, and pyruvate kinase. Together, our data suggest that the aberrant expression of these genes attributes to the mutant clogging phenotype. We propose that these genes can be targeted to foster normal growth in F. velutipes.
Choi, Hyoung Jun;Lee, Jin Won;Choi, Jae Ho;Park, Sung Jae
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
/
v.21
no.4
/
pp.558-567
/
2020
This study examined the defect characteristics of fuel flow proportioner-mounted structures to analyze the causes of structural defects during aircraft operation. System vibrations and single component vibrations that occur during aircraft operations are usually the cause of structural defects. The fuel flow proportioner causes a defect in the support structure due to the vibration caused by the pressure change caused by the sudden increase in the flow rate. Defects in the support structure of the fuel flow proportioner are not correlated directly with the cracking of the maneuver, and flight time according to aircraft operation analysis is related to the use of A/B. The structural reinforcement configuration was confirmed through static and life analysis of the cracks of the bracket mounted under the fuel flow proportioner for improvement of the defect. An analysis of the reinforcement revealed a minimum structural strength of +0.15. Structural life analysis confirmed that the stress acted on the site under 15Ksi. The fatigue life was confirmed to be more than 7,700 Cycles.
Kim, Dong-Seong;Yoo, Min-Young;Kim, Hee-Seong;Choi, Joo-Ho
Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea
/
v.27
no.6
/
pp.635-642
/
2014
In this paper, an efficient technique is developed to predict failure probability of three failure modes(case rupture, fracture and bolt breakage) related to solid rocket motor case due to the inner pressure during the mission flight. The overall procedure consists of the steps: 1) design parameters affecting the case failure are identified and their uncertainties are modelled by probability distribution, 2) combustion analysis in the interior of the case is carried out to obtain maximum expected operating pressure(MEOP), 3) stress and other structural performances are evaluated by finite element analysis(FEA), and 4) failure probabilities are calculated for the above mentioned failure modes. Axi-symmetric assumption for FEA is employed for simplification while contact between bolted joint is accounted for. Efficient procedure is developed to evaluate failure probability which consists of finding first an Most Probable Failure Point(MPP) using First-Order Reliability Method(FORM), next making a response surface model around the MPP using Latin Hypercube Sampling(LHS), and finally calculating failure probability by employing Importance Sampling.
Purpose: The purpose of this study was to identify Radiosensitivity of proteins in tissues with different radiosensitivity. Materials and Methods: C3H/HeJ mice were exposed to 10 Gy. The mice were sacrifiud 8 hrs after radiation. Their spleen and liver tissues were collected and analyzed histologicaly for apoptosis. The expressions of radiosusceptibillty protein were analyzed by 2-dimensional electrophoresis and matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry. Resilts: The Peak of apoptosis levels were $35.3{\pm}1.7{\%}$ in spleen and $0.6{\pm}0.2{\%}$ in liver at 8 hrs after radiation. Liver, radioresistant tissues, showed that the levels of ROS metabolism related to proteins such as cytochromm c, glutathione S transferase, NADH dehydrogenase, riken cDNA and peroxiredoxin Vl increased after radiation. The expression of cytochrome c increased significantly in spleen and liver tissues after radiation. In spleen, radiosensitivity tissue, the identified proteins showed a significantly quantitative alteration following radiation. It was categorized as signal transduction, apoptosis, cytokine, Ca signal related protein, stress-related protein, cytoskeletal regulation, ROS metabolism, and others. Conclusion: Differences of radiation-induced apoptosis by tissues specifted were coupled with the induction of related radiosensitivity and radioresistant proteins. The result suggests that apoptosis relate protein and redox proteins play important roles in this radiosusceptibility.
Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing
/
v.34
no.2
/
pp.155-164
/
2014
Carbon-fiber-reinforced plastic (CFRP) composites are increasingly being used in a variety of industry applications, such as aircraft, automobiles, and ships because of their high specific stiffness and high specific strength. Aircraft are exposed to high temperatures and high humidity for a long duration during flights. CFRP materials of the aircraft can absorb water, which could decrease the adhesion strength of these materials and cause their volumes to change with variation in internal stress. Therefore, it is necessary to estimate the characteristics of CFRP composites under actual conditions from the viewpoint of aircraft safety. In this study air-coupled ultrasonic testing (ACUT) was applied to the evaluation of water absorption properties of CFRP composites. CFRP specimens were fabricated and immersed in distilled water at $75^{\circ}C$ for 30, 60, and 120 days, after which their ultrasonic images were obtained by ACUT. The water absorption properties were determined by quantitatively analyzing the changes in ultrasonic signals. Further, shear strength was applied to the specimens to verify the changes in their mechanical properties for water absorption.
Land Surface Temperature (LST) is one of the useful parameters to diagnose the growth and development of crop and to detect crop stress. Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-based LST (LSTUAV) can be estimated in the regional spatial scale due to miniaturization of thermal infrared camera and development of UAV. Given that meteorological variable, type of instrument, and surface condition can affect the LSTUAV, the evaluation for accuracy of LSTUAV is required. The purpose of this study is to evaluate the accuracy of LSTUAV using LST measured at ground (LSTGround) under various meteorological conditions and growth phases of garlic crop. To evaluate the accuracy of LSTUAV, Relative humidity (RH), absolute humidity (AH), gust, and vegetation index were considered. Root mean square error (RMSE) after minimizing the bias between LSTUAV and LSTGround was 2.565℃ under above 60% of RH, and it was higher than that of 1.82℃ under the below 60% of RH. Therefore, LSTUAV measurement should be conducted under the below 60% of RH. The error depending on the gust and surface conditions was not statistically significant (p-value < 0.05). LSTUAV had reliable accuracy under the wind speed conditions that allow flight and reflected the crop condition. These results help to comprehend the accuracy of LSTUAV and to utilize it in the agriculture field.
Heecheol Park;Jin Wook Baek;Hae Woong Jeong;Young Jin Heo;Suyoung Yun;Ji-Yeon Han
Journal of the Korean Society of Radiology
/
v.84
no.6
/
pp.1361-1366
/
2023
The persistent primitive olfactory artery (PPOA) is a rare variant of the anterior cerebral artery, first reported in 1979. It reportedly has a high correlation with the development of aneurysms, owing to the hemodynamic stress induced by the structural characteristics of the hairpin turn. Herein, we present a rare case of PPOA type 4 with a fusiform aneurysm at the hairpin turn segment in a 46-year-old female with occasional headaches. Time-of-flight MR angiography and transfemoral cerebral angiography revealed an unusual branch arising from the left A1 segment, running anteromedially along the ipsilateral olfactory tract, and turning the hairpin posterior to the olfactory bulb. This branch continued into the left accessory middle cerebral artery, and a fusiform aneurysm was observed at the hairpin segment. No further treatment was performed, and follow-up imaging was recommended. Nevertheless, it is essential to recognize and diagnose these rare variations.
Journal of the Society of Cosmetic Scientists of Korea
/
v.47
no.4
/
pp.361-368
/
2021
The objective of this study was to establish technology for removing bacteria with human- and eco-friendly material. Staphylococcus aureus as an important component for balanced equilibrium among microbiomes, was cultured under various concentrations of phosphate. Experimental observation relating to physical properties was performed in an addition of phosphate buffer. Statistically minimum value of size and hardness using atomic force microscope was observed on the matured biofilm at 5 mM concentration of phosphate. As a result of absorbance for the biofilm tagged with dye, concentration of biofilm was reduced with phophate, too. To identify whether this reduction by phosphate at the 5 mM is caused by counter ion or not, sodium chloride was treated to the biofilm under the same condition. To elucidate components of the biofilm counting analysis of the biofilm using time-of-flight secondary ion mass spectrometry was employed. The secondary ions from the biofilm revealed that alteration of physical properties is consistent to the change of extracellular polymeric substrate (EPS) for the biofilm. Viscoelastic characterization of the biofilm using a controlled shear stress rheometer, where internal change of physical properties could be detected, exhibited a static viscosity and a reduction of elastic modulus at the 5 mM concentration of phosphate. Accordingly, bacteria at the 5 mM concentration of phosphate are attributed to removing the EPS through a reduction of elastic modulus for bacteria. We suggest that the reduction of concentration of biofilm induces dispersion which assists to easily spread its dormitory. In conclusion, it is elucidated that an addition of phosphate causes removal of EPS, and that causes a function of antibiotic.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
[게시일 2004년 10월 1일]
이용약관
제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
이 이용약관은 KoreaScience 홈페이지(이하 “당 사이트”)에서 제공하는 인터넷 서비스(이하 '서비스')의 가입조건 및 이용에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.
제 2 조 (용어의 정의)
① "이용자"라 함은 당 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 당 사이트가 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을
말합니다.
② "회원"이라 함은 서비스를 이용하기 위하여 당 사이트에 개인정보를 제공하여 아이디(ID)와 비밀번호를 부여
받은 자를 말합니다.
③ "회원 아이디(ID)"라 함은 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 자신이 선정한 문자 및 숫자의 조합을
말합니다.
④ "비밀번호(패스워드)"라 함은 회원이 자신의 비밀보호를 위하여 선정한 문자 및 숫자의 조합을 말합니다.
제 3 조 (이용약관의 효력 및 변경)
① 이 약관은 당 사이트에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
② 당 사이트는 이 약관을 개정할 경우에 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 당 사이트의
초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하게 약관내용을
변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 당 사이트는 개정 전
내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.
제 4 조(약관 외 준칙)
① 이 약관은 당 사이트가 제공하는 서비스에 관한 이용안내와 함께 적용됩니다.
② 이 약관에 명시되지 아니한 사항은 관계법령의 규정이 적용됩니다.
제 2 장 이용계약의 체결
제 5 조 (이용계약의 성립 등)
① 이용계약은 이용고객이 당 사이트가 정한 약관에 「동의합니다」를 선택하고, 당 사이트가 정한
온라인신청양식을 작성하여 서비스 이용을 신청한 후, 당 사이트가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
② 제1항의 승낙은 당 사이트가 제공하는 과학기술정보검색, 맞춤정보, 서지정보 등 다른 서비스의 이용승낙을
포함합니다.
제 6 조 (회원가입)
서비스를 이용하고자 하는 고객은 당 사이트에서 정한 회원가입양식에 개인정보를 기재하여 가입을 하여야 합니다.
제 7 조 (개인정보의 보호 및 사용)
당 사이트는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원 등록정보를 포함한 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 회원 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 당 사이트의 개인정보 보호정책이 적용됩니다.
제 8 조 (이용 신청의 승낙과 제한)
① 당 사이트는 제6조의 규정에 의한 이용신청고객에 대하여 서비스 이용을 승낙합니다.
② 당 사이트는 아래사항에 해당하는 경우에 대해서 승낙하지 아니 합니다.
- 이용계약 신청서의 내용을 허위로 기재한 경우
- 기타 규정한 제반사항을 위반하며 신청하는 경우
제 9 조 (회원 ID 부여 및 변경 등)
① 당 사이트는 이용고객에 대하여 약관에 정하는 바에 따라 자신이 선정한 회원 ID를 부여합니다.
② 회원 ID는 원칙적으로 변경이 불가하며 부득이한 사유로 인하여 변경 하고자 하는 경우에는 해당 ID를
해지하고 재가입해야 합니다.
③ 기타 회원 개인정보 관리 및 변경 등에 관한 사항은 서비스별 안내에 정하는 바에 의합니다.
제 3 장 계약 당사자의 의무
제 10 조 (KISTI의 의무)
① 당 사이트는 이용고객이 희망한 서비스 제공 개시일에 특별한 사정이 없는 한 서비스를 이용할 수 있도록
하여야 합니다.
② 당 사이트는 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 구축하며 개인정보 보호정책을 공시하고 준수합니다.
③ 당 사이트는 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 객관적으로 인정될 경우에는 적절한 절차를
거쳐 즉시 처리하여야 합니다. 다만, 즉시 처리가 곤란한 경우는 회원에게 그 사유와 처리일정을 통보하여야
합니다.
제 11 조 (회원의 의무)
① 이용자는 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며,
허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 일체의 권리를 주장할 수 없습니다.
② 당 사이트가 관계법령 및 개인정보 보호정책에 의거하여 그 책임을 지는 경우를 제외하고 회원에게 부여된
ID의 비밀번호 관리소홀, 부정사용에 의하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
③ 회원은 당 사이트 및 제 3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다.
제 4 장 서비스의 이용
제 12 조 (서비스 이용 시간)
① 서비스 이용은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 운영을
원칙으로 합니다. 단, 당 사이트는 시스템 정기점검, 증설 및 교체를 위해 당 사이트가 정한 날이나 시간에
서비스를 일시 중단할 수 있으며, 예정되어 있는 작업으로 인한 서비스 일시중단은 당 사이트 홈페이지를
통해 사전에 공지합니다.
② 당 사이트는 서비스를 특정범위로 분할하여 각 범위별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만
이 경우 그 내용을 공지합니다.
제 13 조 (홈페이지 저작권)
① NDSL에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, KISTI는 복제/배포/전송권을 확보하고
있습니다.
② NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 상업적 및 기타 영리목적으로 복제/배포/전송할 경우 사전에 KISTI의 허락을
받아야 합니다.
③ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에
합치되게 인용할 수 있습니다.
④ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우
저작권법 제136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
제 14 조 (유료서비스)
① 당 사이트 및 협력기관이 정한 유료서비스(원문복사 등)는 별도로 정해진 바에 따르며, 변경사항은 시행 전에
당 사이트 홈페이지를 통하여 회원에게 공지합니다.
② 유료서비스를 이용하려는 회원은 정해진 요금체계에 따라 요금을 납부해야 합니다.
제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 15 조 (계약 해지)
회원이 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 [가입해지] 메뉴를 이용해 직접 해지해야 합니다.
제 16 조 (서비스 이용제한)
① 당 사이트는 회원이 서비스 이용내용에 있어서 본 약관 제 11조 내용을 위반하거나, 다음 각 호에 해당하는
경우 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.
- 2년 이상 서비스를 이용한 적이 없는 경우
- 기타 정상적인 서비스 운영에 방해가 될 경우
② 상기 이용제한 규정에 따라 서비스를 이용하는 회원에게 서비스 이용에 대하여 별도 공지 없이 서비스 이용의
일시정지, 이용계약 해지 할 수 있습니다.
제 17 조 (전자우편주소 수집 금지)
회원은 전자우편주소 추출기 등을 이용하여 전자우편주소를 수집 또는 제3자에게 제공할 수 없습니다.
제 6 장 손해배상 및 기타사항
제 18 조 (손해배상)
당 사이트는 무료로 제공되는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의 또는 과실로 인한 손해발생을 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
제 19 조 (관할 법원)
서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 민사 소송법상의 관할 법원에 제기합니다.
[부 칙]
1. (시행일) 이 약관은 2016년 9월 5일부터 적용되며, 종전 약관은 본 약관으로 대체되며, 개정된 약관의 적용일 이전 가입자도 개정된 약관의 적용을 받습니다.