Chromosome condensation and swelling of the donor nucleus have been known as the early morphological indicators of chromatin remodelling after injection of a foreign nucleus into an enucleated recipient cytoplasm. The effects of non-preactivation and electrical preactivation of recipient cytoplasm, prior to fusing a donor nucleus, on the profile of nuclear remodelling in the nuclear transplant rabbit embryos were evaluated. The embryos of 16-cell stage were collected and synchronized to G1 phase of 32-cell stage. The recipient cytoplasms were obtained by removing the first polar body and chromosome mass by non-disruptive microsurgical procedure. The separated G1 phase blastomeres of 32-cell stage were injected into non-preactivated recipient cytoplasms. Otherwise, the enucleated recipient cytoplasms were preactivated by electrical stimulation and the separated G1 phase blastomeres of 32-cell stage were injected. After culture until 20h post-hCG injection, the nuclear transplant oocytes were electrofused by electrical stimulation. The nuclei of nuclear transplant embryos fused into non-preactivated and/or preactivated recipient cytoplasm were stained by Hoechst 33342 at 0, 1.5, 2, 4, 6, 8, 10 hrs post-fusion and were observed under an fluorescence microscopy. Accurate measurements of nuclear diameter were revealed with an ocular micrometer at 200$\times$. Upon blastomere fusion into non-preactivated recipient cytoplasm, a prematurely chromosome condensation at 1.5 hrs post-fusion and nuclear swelling at 8 hrs post-fusion were occurred as 91.6% and 86.1%, respectively. But the nuclei of nuclear transplant embryos fused into preactivated recipient cytoplasm, as o, pp.sed to non-preactivated recipient cytoplasm, were not occurred chromosome condensation and extensive nuclear swelling. Nuclear diameter fused into non-preactivated and preactivated recipient cytoplasm at hrs post-fusion was 30.2$\pm$0.74 and 15.2$\pm$1.32${\mu}{\textrm}{m}$, respectively. These results indicated that onset of unclear condensation and swelling which was associated with oocytes activation were critical steps in the process of chromatin swelling. Futhermore, complete reprogramming seemed only possible after remodelling of the donor nucleus by chromosome condensation and nuclear swelling.
Condensin is not only responsible for chromosome condensation, but is also involved in double-strand break (DSB) processing in the cell cycle. During meiosis, the condensin complex serves as a component of the meiotic chromosome axis, and mediates both proper assembly of the synaptonemal complex and DSB repair, in order to ensure proper homologous chromosome segregation. Here, we used the budding yeast Saccharomyces cerevisiae to show that condensin participates in a variety of chromosome organization processes and exhibits crucial molecular functions that contribute to meiotic recombination during meiotic prophase I. We demonstrate that Ycs4 is required for efficient DSB formation and establishing homolog bias at the early stage of meiotic prophase I, which allows efficient formation of interhomolog recombination products. In the Ycs4 meiosis-specific allele (ycs4S), interhomolog products were formed at substantial levels, but with the same reduction in crossovers and noncrossovers. We further show that, in prophase chromosomal events, ycs4S relieved the defects in the progression of recombination interactions induced as a result of the absence of Rec8. These results suggest that condensin is a crucial coordinator of the recombination process and chromosome organization during meiosis.
Equisetum arvense L. and Lactuca dentata Makino. var. Flaviflora Makino. of samples relatively showed anticancer effects on MCF-7 mammary gland adenocarcinoma cell. The most active plant among the samples was Capsicum annuum L. var angulosum Mill. We studied that MCF-7 cells were changing chromosomal morphology and apoptosis on these samples. Capsicum annuum L. var. angulosum Mill. of samples relatively showed good anticancer effects. The cells became vague after 2 days and then destroyed. The supernatant of the cells including medium was measured by UV absorbance. The results showed that Capsicum annuum L. var. angulosum Mill also exerted high level. We also used electrophoresis in order to observe apoptic characterization of DNA fragmentation. The cells treated with Capsicum annuum L. var. angulosum Mill showed the apoptotic characterization. The chromosome of the cells were observed on those samples. The cells treated with Capsicum annuum L. var. angulosum Mill among them were shown the fastest changes. The cells were aggregated and destroyed by treatment with some edible plants. Especially, the case of Capsicum annuum L. var. angulosum Mill, it led MCF-7 cell to apoptosis faster than others. And we can observe chromosomal changes and dispersion by PI staining. These results showed that each sample exerted anticancer effects on MCF-7 cells. Especially Capsicum annuum L. var. angulosum Miff exerted significant anticancer effects.
Despite of importance of integrated events of nucleus and microtubule remodeling in nuclear transferred embryos with somatic cells, little information is available on this subject. In this study we configured chromatin and microtubule organization following somatic cell nuclear transfer in pre- and non-activated bovine oocytes in order to clearify nuclear remodeling process and to demonstrate centrosome inheritance during nuclear transfer. The cumulus-oocyte complexes were collected from slaughterhouse and were matured in vitro for 20 h in TCM 199 supplemented hormone. Matured bovine oocytes were enucleated by aspirating the frist polar body and metaphase chromatin using a beveled pipette. Bovine fibroblast cells were fused into enucleated oocyte by electrical stimulation. Reconstructed oocytes were activated with ionomycine and 6-dimethylaminopurin, and then cultured in CRlaa medium. The organization of nuclear and microtubules were observed using laser-scanning confocal microscopy. At 1 hour after fusion, microtubule aster was seen near the transferred nucleus in most oocytes regardless activation condition. While most of fibroblast nuclei remodeled to premature chromosome condensation (PCC) and to the two masses of chromosome in non-activated oocytes, a few number of fibloblasts went to PCC and multiple pronuclear like structures in activated oocytes. Microtubular spindle was seen around condensed chromosome. Gamma-tubulin was detected in the vicinity of condensed chromosome, suggesting this is a transient spindle. The spindle seperated nucleus into two masses of chromatin which developed to the pronuclear like structures. Two pronuclear like structures were than apposed by microtubular aster and formed one syngamy like nuclear structure at 15 h following nuclear transfer. At 17 to 18 h after fusion, two centrosomes were seen near the nucleus, which nucleates micrtubules for two cell cleavage. While 31% of reconstructed oocytes in non-activated condition developed to morulae and blastocysts, a few reconstructed oocytes in pre-activated condition developed to the blastocyst. These results suggested introduction of foreign centrosome during nuclear transfer, which appeared to give an important role for somatic cell nuclear reprogramming.
This study was carried out to identify the chromosome morphological structure and G-, C-banding pattern of Korean native fowl. The samples used in this study were early chick embryos, and the method of chromosomal analysis quoted from the protocal of Ohio univ. with more or less modified. The results were summerized as follow as; 1. In each of macrochromosomal morphology, the arm-ratio, centromeric index, and relative length of Korean native fowl were more or less different from improved breeds, but the designations were the same. 2. The graphical pecks, by densitometric recordings, in each macrochromosome number of 1, 2, 3, 4, Z, and 5, numbered 21, 14, 12, 8, 11, and 4 in G-banded, and 16, 13, 9, 9, 9, and 4 in C-banded, respectively. Those pecks could be explained as a consequence of chromosome condensation during mitosis and of genetic material differences.
Using topoisomerase II (topo II) isozyme-specific antibodies, we investigated the phosphorylation of topo $II{\alpha}$ in mitotic HeLa cells. Topo $II{\alpha}$ was specifically modified in the mitotic cells, resulting in slow migration on SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. To characterize the nature of this modification, we treated the nuclear extracts prepared from the mitotic cells with alkaline phosphatase. After the treatment with alkaline phosphatase, the slowly migrated band disappeared and instead a normal (170 kDa) topo $II{\alpha}$ band appeared. These results indicate that human topo $II{\alpha}$ is modified at a specific site(s) in M phase by phosphorylation, supporting the possibility that M phase-specific phosphorylation of topo II is critical for mitotic chromosome condensation and segregation.
In order to study the cytotoxic properties of sesquitepenes, dehydrocostus lactone (DL) and costunolide from Saussurea lappa, cytotoxicity was measured by SRB method using various human cancer cell lines. Dehydrocostus lactone(DL) and costunolide exhibited significant cytotoxicity against A-549, SK-OV-3, SK-MEL-2, XF-498 and HCT 15 cells. The U937 human leukemia cells treated with DL showed several apoptotic evidences like chromosome condensation and formation of apoptotic bodies. From the results of FACS analysis, early apoptosis was observed by phosphatidylserine externalization detected by annexin V-FITC. Furethermore, these studies determined hypodiploid contents and effects on the cell phase distribution of DL-treated U937 cells. After exposure of U937 cells to $30\mu\textrm{M}$ DL effectively led to G2/M modified cell cycle distribution within 24hr. These observations suggest that DL can be used efficiently for the cancer treatment.
Mitochondria are important sensor of apoptosis. $H_2O_2-induced$ cell death rate was enhanced by serum deprivation. In this study, we investigated whether serum deprivation using 0.5 or 3 % FBS induces apoptotic cell death through mitochondrial enzyme activation as compared to 10 % FBS. Apoptotic cell death was observed by chromosome condensation and the increase of sub-G0/G1 population. Serum deprivation reduced cell growth rate, which was confirmed by the decrease of S-phase population in cell cycle. Serum deprivation significantly increased caspase-9 activity and cytochrome c release from mitochondria into cytosol. Serum deprivation-induced mitochondrial changes were also indicated by the increase of ROS production and the activation of mitochondrial enzyme, succinate dehydrogenase. Mitochondrial enzyme activity increased by serum deprivation was reduced by the treatment with rotenone, mitochondrial electron transport inhibitor. In conclusion, serum deprivation induced mitochondrial apoptotic cell death through the elevation of mitochondrial changes such as ROS production, cytochrome c release and caspase-9 activation. It suggests that drug sensitivity could be enhanced by the increase of mitochondrial enzyme activity in serum-deprived condition.
Hydroxyurea (HU), a DNA synthesis inhibitor, was tested as synchronizing agent in root-tip meristem of Allium wakegi. Roots were treated with 2.5mM HU for 14 h to accumulate meristem root-tip cells at the G1/S interface. After release from HU block, the cells re-entered the cell cycle with a high degree of synchrony. Synchronized mitotic frequency of A. wakegi was 22.7%, which was about 3.9 times as high as that of the control. The highest metaphase index(23.0%) was obtained when, 6 h after release from the HU block, the roots were treated with 0.05% colchicine for 2 h. Modifying various Giemsa staining protocols defined for animals and a few plant species, G-bands were visualized at prometaphase and metaphase chromosomes of A. wakegi. The higher degree of chromosome condensation, the less differential bands could be resolved. This is the first demonstration introduced partial mitotic synchronization into G-banding in plant.
The anti-proliferating effects of some plants on hepatoma cell lines were studied by the 3-[4,5-dim-ethylthiazol-2yl]-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT assay), to investigate the anticancer effect with some plants around here. As the result, we saw that the anti-prolferating effect to the plants. Among the plants, Equisetum arvense L. and Lactuca dentata Makino. var, flaviflora Makino of them relatively showed a good ant-proliferating effect. Capsicum annuum L. var. angulosum Mill (Leaf) was the best among them. We also examined morphological changes on the hepatoma cells in this process. In case of Capxicum annuum L. var. angulosum Mill, the tells become vague after 2 days, and then destroyed faster than others. We can fee also the condensated chromosome on the treated cells with Capxicum annuum L. var. angulosum Mill. And we also observed condensation through using a fluorescent microscope by PI staining, and observed DNA fragmentation.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
[게시일 2004년 10월 1일]
이용약관
제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
이 이용약관은 KoreaScience 홈페이지(이하 “당 사이트”)에서 제공하는 인터넷 서비스(이하 '서비스')의 가입조건 및 이용에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.
제 2 조 (용어의 정의)
① "이용자"라 함은 당 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 당 사이트가 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을
말합니다.
② "회원"이라 함은 서비스를 이용하기 위하여 당 사이트에 개인정보를 제공하여 아이디(ID)와 비밀번호를 부여
받은 자를 말합니다.
③ "회원 아이디(ID)"라 함은 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 자신이 선정한 문자 및 숫자의 조합을
말합니다.
④ "비밀번호(패스워드)"라 함은 회원이 자신의 비밀보호를 위하여 선정한 문자 및 숫자의 조합을 말합니다.
제 3 조 (이용약관의 효력 및 변경)
① 이 약관은 당 사이트에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
② 당 사이트는 이 약관을 개정할 경우에 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 당 사이트의
초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하게 약관내용을
변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 당 사이트는 개정 전
내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.
제 4 조(약관 외 준칙)
① 이 약관은 당 사이트가 제공하는 서비스에 관한 이용안내와 함께 적용됩니다.
② 이 약관에 명시되지 아니한 사항은 관계법령의 규정이 적용됩니다.
제 2 장 이용계약의 체결
제 5 조 (이용계약의 성립 등)
① 이용계약은 이용고객이 당 사이트가 정한 약관에 「동의합니다」를 선택하고, 당 사이트가 정한
온라인신청양식을 작성하여 서비스 이용을 신청한 후, 당 사이트가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
② 제1항의 승낙은 당 사이트가 제공하는 과학기술정보검색, 맞춤정보, 서지정보 등 다른 서비스의 이용승낙을
포함합니다.
제 6 조 (회원가입)
서비스를 이용하고자 하는 고객은 당 사이트에서 정한 회원가입양식에 개인정보를 기재하여 가입을 하여야 합니다.
제 7 조 (개인정보의 보호 및 사용)
당 사이트는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원 등록정보를 포함한 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 회원 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 당 사이트의 개인정보 보호정책이 적용됩니다.
제 8 조 (이용 신청의 승낙과 제한)
① 당 사이트는 제6조의 규정에 의한 이용신청고객에 대하여 서비스 이용을 승낙합니다.
② 당 사이트는 아래사항에 해당하는 경우에 대해서 승낙하지 아니 합니다.
- 이용계약 신청서의 내용을 허위로 기재한 경우
- 기타 규정한 제반사항을 위반하며 신청하는 경우
제 9 조 (회원 ID 부여 및 변경 등)
① 당 사이트는 이용고객에 대하여 약관에 정하는 바에 따라 자신이 선정한 회원 ID를 부여합니다.
② 회원 ID는 원칙적으로 변경이 불가하며 부득이한 사유로 인하여 변경 하고자 하는 경우에는 해당 ID를
해지하고 재가입해야 합니다.
③ 기타 회원 개인정보 관리 및 변경 등에 관한 사항은 서비스별 안내에 정하는 바에 의합니다.
제 3 장 계약 당사자의 의무
제 10 조 (KISTI의 의무)
① 당 사이트는 이용고객이 희망한 서비스 제공 개시일에 특별한 사정이 없는 한 서비스를 이용할 수 있도록
하여야 합니다.
② 당 사이트는 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 구축하며 개인정보 보호정책을 공시하고 준수합니다.
③ 당 사이트는 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 객관적으로 인정될 경우에는 적절한 절차를
거쳐 즉시 처리하여야 합니다. 다만, 즉시 처리가 곤란한 경우는 회원에게 그 사유와 처리일정을 통보하여야
합니다.
제 11 조 (회원의 의무)
① 이용자는 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며,
허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 일체의 권리를 주장할 수 없습니다.
② 당 사이트가 관계법령 및 개인정보 보호정책에 의거하여 그 책임을 지는 경우를 제외하고 회원에게 부여된
ID의 비밀번호 관리소홀, 부정사용에 의하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
③ 회원은 당 사이트 및 제 3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다.
제 4 장 서비스의 이용
제 12 조 (서비스 이용 시간)
① 서비스 이용은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 운영을
원칙으로 합니다. 단, 당 사이트는 시스템 정기점검, 증설 및 교체를 위해 당 사이트가 정한 날이나 시간에
서비스를 일시 중단할 수 있으며, 예정되어 있는 작업으로 인한 서비스 일시중단은 당 사이트 홈페이지를
통해 사전에 공지합니다.
② 당 사이트는 서비스를 특정범위로 분할하여 각 범위별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만
이 경우 그 내용을 공지합니다.
제 13 조 (홈페이지 저작권)
① NDSL에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, KISTI는 복제/배포/전송권을 확보하고
있습니다.
② NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 상업적 및 기타 영리목적으로 복제/배포/전송할 경우 사전에 KISTI의 허락을
받아야 합니다.
③ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에
합치되게 인용할 수 있습니다.
④ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우
저작권법 제136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
제 14 조 (유료서비스)
① 당 사이트 및 협력기관이 정한 유료서비스(원문복사 등)는 별도로 정해진 바에 따르며, 변경사항은 시행 전에
당 사이트 홈페이지를 통하여 회원에게 공지합니다.
② 유료서비스를 이용하려는 회원은 정해진 요금체계에 따라 요금을 납부해야 합니다.
제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 15 조 (계약 해지)
회원이 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 [가입해지] 메뉴를 이용해 직접 해지해야 합니다.
제 16 조 (서비스 이용제한)
① 당 사이트는 회원이 서비스 이용내용에 있어서 본 약관 제 11조 내용을 위반하거나, 다음 각 호에 해당하는
경우 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.
- 2년 이상 서비스를 이용한 적이 없는 경우
- 기타 정상적인 서비스 운영에 방해가 될 경우
② 상기 이용제한 규정에 따라 서비스를 이용하는 회원에게 서비스 이용에 대하여 별도 공지 없이 서비스 이용의
일시정지, 이용계약 해지 할 수 있습니다.
제 17 조 (전자우편주소 수집 금지)
회원은 전자우편주소 추출기 등을 이용하여 전자우편주소를 수집 또는 제3자에게 제공할 수 없습니다.
제 6 장 손해배상 및 기타사항
제 18 조 (손해배상)
당 사이트는 무료로 제공되는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의 또는 과실로 인한 손해발생을 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
제 19 조 (관할 법원)
서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 민사 소송법상의 관할 법원에 제기합니다.
[부 칙]
1. (시행일) 이 약관은 2016년 9월 5일부터 적용되며, 종전 약관은 본 약관으로 대체되며, 개정된 약관의 적용일 이전 가입자도 개정된 약관의 적용을 받습니다.