ZAS3 is a large zinc finger transcription repressor that binds the ${\kappa}B$-motif via two signature domains of ZASN and ZASC. A loss-of-function study showed that lack of ZAS3 protein induced accelerated cell proliferation and tumorigenesis. Conversely, gain-of-function studies showed that ZAS3 repressed $NF{\kappa}B$-activated transcription by competing with $NF{\kappa}B$ for the ${\kappa}B$-motif. Based on these observations, we hypothesize that ZAS3 promotes apoptosis by interrupting anti-apoptotic activity of $NF{\kappa}B$. Here, we present evidence that upon $TNF{\alpha}$ stimulation, ZAS3 inhibits $NF{\kappa}B$-mediated cell survival and promotes caspase-mediated apoptosis. The inhibitory effect of ZAS3 on $NF{\kappa}B$ activity is mediated by neither direct association with $NF{\kappa}B$ nor disrupting nuclear localization of $NF{\kappa}B$. Instead, ZAS3 repressed the expression of two key anti-apoptotic genes of $NF{\kappa}B$, TRAF1 and TRAF2, thereby sensitizing cells to $TNF{\alpha}$-induced cell death. Taken together, our data suggest that ZAS3 is a tumor suppressor gene and therefore serves as a novel therapeutic target for developing anti-cancer drugs.
Park, Yong-Sook;Jeon, Byung-Chan;Oh, Hyung-Suk;Lee, Seok-Mo;Chun, Bong-Kwon;Chang, Hee-Kyung
Journal of Korean Neurosurgical Society
/
v.40
no.6
/
pp.428-433
/
2006
Objective : We investigated the pattern of glucose uptake in meningiomas using $^{18}F$-fluoro-2-deoxy-D-glucose[FDG] PET/CT. It was hypothesized that the degree of glucose uptake in each tumor could predict the histologic grade. Methods : In 19 patients with meningiomas, the Ki-67 proliferative index, standardized uptake values[SUV] of FDG uptake, tumor to contralateral gray matter ratio[TGR] of SUV, tumor size, edema grade, vascular endothelial growth factor[VEGF] expression, histopathologic grade and the blood supply pattern were assessed. Results : Of the 19 meningiomas, 8 were meningothelial, 1 fibrous, 2 transitional, 1 psammomatous, 2 angiomatous, and 5 atypical. The tumor proliferative index of Ki-67, tumor size, and peritumoral edema were larger in the histopathologic grade-2 meninigiomas than in the grade-1 meningioma group. There were no significant differences in SUV and TGR between two groups. Tumor size and peritumoral edema were significantly larger in VEGF-positive tumors than in negative tumors. Conventional angiography was performed in 12 patients. Dural supply was noted predominantly in 2 patients. Four patients had mainly pial cortical supply patterns. In tumors with more pial supply, VEGF was more frequently positive. There was a significant relation between SUV and Ki-67 and between SUV and peritumoral edema. Conclusion : We found FOG uptake in meningiomas is associated with proliferative potential, however, no clear limits of SUV and TGR can be set to distinguish between grade-1 and grade-2 meningiomas, which makes the assessment of malignancy grade using PET scan metabolic imaging difficult in individual cases.
BACKGROUND/OBJECTIVES: Excessive intake of simple sugars induces obesity and increases the risk of inflammation. Thus, interest in alternative sweeteners as a sugar substitute is increasing. The purpose of this study was to determine the effect of saccharin on inflammation in 3T3-L1 adipocytes. MATERIALS/METHODS: 3T3-L1 preadipocytes were differentiated into adipocytes. The adipocytes were treated with saccharin (0, 50, 100, and 200 ㎍/mL) for 24 h. Inflammation was induced by exposure of treated adipocytes to lipopolysaccharide (LPS) for 18 h and cell proliferation was measured. The concentration of nitric oxide (NO) was measured by using Griess reagent. Protein expressions of nuclear factor kappa B (NF-κB) and inhibitor κB (IκB) were determined by western blot analysis. The mRNA expressions of inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase-2 (COX-2), interleukin 1β (IL-1β), interleukin 6 (IL-6), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), and tumor necrosis factor-α (TNF-α) were determined by real-time PCR. RESULTS: Compared with the control group, the amount of NO and the mRNA expression of iNOS in the LPS-treated group were increased by about 17.6% and 46.9%, respectively, (P < 0.05), and those parameter levels were significantly decreased by saccharin treatment (P < 0.05). Protein expression of NF-κB was decreased and that of IκB was increased by saccharin treatment (P < 0.05). Saccharin decreased the mRNA expression of COX-2 and the inflammation cytokines (IL-1β, IL-6, MCP-1, and TNF-α) (P < 0.05). CONCLUSIONS: The results of this study suggest that saccharin can inhibit LPS-induced inflammatory responses in 3T3-L1 adipocytes via the NF-κB pathway.
Steroid hormone is known to cause the dynamic changes of mammalian uterus during reproductive cycle. However there is little information about the effect of estrogen (E) and progesterone (P) on the expression of various transcription factors involved in gene expression. Thus the present study was designed to demonstrate E and/or P-induced expression of c-Fos, CREB, ATF and HSP70 in rat uterus. Rats, ovariectomized (OVX) for two weeks, were divided into 6 experimental groups, 1) OVX, 2) OVX+V, 3) OVX+E, 4) OVX+P, 5) OVX+E+V, 6) OVX+E+P, and western blotting assay for nuclear extract and immunohistochemical staining were carried out for each experimental group. Treatment of E $(10{\mu}g)$ showed to increase the expression of c-Fos, CREB, ATF, and HSP70, and maximal expression was occured at $3\sim6$ hr after E administration. P (1mg) also increased, but much less than E, the expression of c-Fos, ATF, and HSP70. However, P did not reveal any effect on the expression CREE. P treatment 4 hr after E injection decreased c-Fos, CREB, and ATF expression, but did not show any change in the E-induced HSP70 expression. In immunohistochemical study c-Fos-, CREB-, and ATF-immunoreactivities were confined to the cells of luminal epithelium of uterine endometrium. These results suggest that proliferation and differentiation of rat uterus during reproductive cycle may mediated via expression of transcription factors, such as c-Fos, CREB, ATF, and HSP70.
The present study investigated an effect of arsenic trioxide on the urethane-induced lung carcinogenesis in mice. To understand its carcinogenesis, we examined proliferating cell nuclear antigen (PCNA), apoptotic index as well as cell cycle-related proteins (cyclin D1, p21, and p27). Urethane was injected intraperitoneally in ICR mice, and then they were sacrificed at 5, 15, or 25 weeks following treatment of arsenic trioxide. Arsenic trioxide was given with tap water at a concentration of 1 mg/l (low-dose) and 5mg/1 (high-dose) for 25 weeks. During the carcinogenesis, sequential histological changes from hyperplasia to adenomas, and ultimately to overt carcinomas were noted. The development of hyperplasias, adenomas, and carcinomas in the lung were slightly increased by the treatment of low-dose arsenic trioxide. However, there is no correlation between dose and tumor multiplicity. The administration of low-dose arsenic trioxide, significantly increased the tumor size. The proliferative index observed on 5 weeks after significantly increased. Cyclin D1 and p21 protein, cell cycle related proteins, were more significantly increased in hyperplasia and adenoma in low dose arsenic treated group than urethane alone group. The p27 protein expression did not show any significantly changes with arsenic treated or untreated group. Low dose exposure to arsenic trioxide resulted in increased expression of cyclin D1 and p21 protein. The present results indicate that low-dose treatment of arsenic trioxide, but not high dose of it, partly modulate the cellular proliferation, cyclin D1, and p21 protein expression, and that this effect may contribute to accelerated development of lung adenocarcinomas in urethane-induced mice.
The study was performed to investigate the histological findings and the appearances of positive cells by immunohistochemical methods using proliferating cell nuclear antigen (PCNA) antibody and apoptotic kit in diethylnitrosamine (DEN) -induced rat liver cancer model. Forty four male rats (Sprague Dawley), initially 5 to 6 weeks of age and 120 to 150gm in body weight were continuously were given with water containing 0.01% DEN for 13 weeks and 3~6 rats per week were randomly sacrified at intervals of a week from 8 weeks to 17 weeks. The interlobular connective tissues in the rat livers were proliferated at early 8 weeks. The vaccuolated or fatty degenerated liver cells were focally distributed and then widely distributed with the passage of weeks and the liver cells with large vacuoles tended to be crowded in focal areas, and the liver cells in some lobules were transformed into small or eosinophilic polyhedral large cells. The hepatocellular carcinoma and the cholangiocarcinoma were simultaneously developed in same liver and tended to be markedly developed after 12 weeks but the development of carcinoma in some livers at same week were less or more advanced as 3~5 week intervals. The regions with more number of positive cells by PCNA antibody or apoptotic kits in livers were ranked as following order ; small hepatocellular carcinoma regions, cholangiocarcinoma regions, trabecular or acinar type carcinoma regions, and large liver cell regions. The numbers of the positive cells by PCNA antibody were more numerous than those by apoptotic kit. So these findings suggested that the volumes and weights of the livers were increasing by more many proliferating of carcinoma cells on the above ordered regions.
Abdel-Rahman, Salah;Shaban, Nadia;Haggag, Amany;Awad, Doaa;Bassiouny, Ahmad;Talaat, Iman
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
/
v.16
no.18
/
pp.8411-8418
/
2016
The effect of Eruca sativa seed extract (SE) on nuclear factor kappa B (NF-${\kappa}B$), cyclooxygenase-2 (COX-2) and B-cell lymphoma-2 (Bcl-2) gene expression levels was investigated in rat mammary gland carcinogenesis induced by 7,12 dimethylbenz(${\alpha}$)anthracene (DMBA). DMBA increased NF-${\kappa}B$, COX-2 and Bcl-2 gene expression levels and lipid peroxidation (LP), while, decreased glutathione-S-transferase (GST) and superoxide dismutase (SOD) activities and total antioxidant concentration (TAC) compared to the control group. After DMBA administration, SE treatment reduced NF-${\kappa}B$, COX-2 and Bcl-2 gene expression levels and LP. Hence, SE treatment reduced inflammation and cell proliferation, while increasing apoptosis, GST and SOD activities and TAC. Analysis revealed that SE has high concentrations of total flavonoids, triterpenoids, alkaloids and polyphenolic compounds such as gallic, chlorogenic, caffeic, 3,4-dicaffeoyl quinic, 3,5-dicaffeoyl quinic, tannic, cinnamic acids, catechin and phloridzin. These findings indicate that SE may be considered a promising natural product from cruciferous vegetables against breast cancer, especially given its high antioxidant properties.
Shikonin, a major ingredient in the traditional Chinese herb Lithospermumerythrorhizon, exhibits multiple biological functions including antimicrobial, anti-inflammatory, and antitumor effects. It has recently been reported that shikonin displays antitumor properties in many cancers. This study was aimed to investigate whether shikonin could inhibit oral squamous carcinoma cell (OSCC) growth via mechanisms of apoptosis and cell cycle arrest. The effects of shikonin on the viability and growth of OSCC cell line, SCC25 cells were assessed by MTT assay and clonogenic assays, respectively. Hoechst staining and DNA electrophoresis indicated that the shikonin-treated SCC25 cells were undergoing apoptosis. Western blotting, immunocytochemistry, confocal microscopy, flow cytometry, MMP activity, and proteasome activity also supported the finding that shikonin induces apoptosis. Shikonin treatment of SCC25 cells resulted in a time- and dose-dependent decrease in cell viability, inhibition of cell growth, and increase in apoptotic cell death. The treated SCC25 cells showed several lines of apoptotic manifestation as follows: nuclear condensation; DNA fragmentation; reduced MMP and proteasome activity; decrease in DNA contents; release of cytochrome c into cytosol; translocation of AIF and DFF40 (CAD) onto the nuclei; a significant shift in Bax/Bcl-2 ratio; and activation of caspase-9, -7, -6, and -3, as well as PARP, lamin A/C, and DFF45 (ICAD). Shikonin treatment also resulted in down-regulation of the G1 cell cycle-related proteins and up-regulation of $p27^{KIP1}$. Taken together, our present findings demonstrate that shikonin strongly inhibits cell proliferation by modulating the expression of the G1 cell cycle-related proteins, and that it induces apoptosis via the proteasome, mitochondria, and caspase cascades in SCC25 cells.
Few studies have evaluated the apoptosis-inducing efficacy of NaF on cancer cells in vitro but there has been no previous investigation of the apoptotic effects of NaF on human oral squamous cell carcinoma cells. In this study, we have investigated the mechanisms underlying the apoptotic response to NaF treatment in the YD9 human squamous cell carcinoma cell line. The viability of YD9 cells and their growth inhibition were assessed by MTT and clonogenic assays, respectively. Hoechst staining, DNA electrophoresis and TUNEL staining were conducted to detect apoptosis. YD9 cells were treated with NaF, and western blotting, immunocytochemistry, confocal microscopy, FACScan flow cytometry, and MMP and proteasome activity assays were performed sequentially. The NaF treatment resulted in a time- and dose-dependent decrease in YD9 cell viability, a dose-dependent inhibition of cell growth, and the induction of apoptotic cell death. The apoptotic response of these cells was manifested by nuclear condensation, DNA fragmentation, the reduction of MMP and proteasome activity, a decreased DNA content, the release of cytochrome c into the cytosol, the translocation of AIF and DFF40 (CAD) into the nucleus, a significant shift of the Bax/Bcl-2 ratio, and the activation of caspase-9, caspase-3, PARP, Lamin A/C and DFF45 (ICAD). Furthermore, NaF treatment resulted in the downregulation of G1 cell cyclerelated proteins, and upregulation of p53 and the Cdk inhibitor $p27^{KIP1}$. Taken collectively, our present findings demonstrate that NaF strongly inhibits YD9 cell proliferation by modulating the expression of G1 cell cycle-related proteins and inducing apoptosis via mitochondrial and caspase pathways.
Several studies have shown that curcumin, which is derived from the rhizomes of turmeric, possesses antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory properties. The antitumor properties of curcumin have also now been demonstrated more recently in different cancers. This study was undertaken to investigate the modulation of cell cycle-related proteins and the mechanisms underlying apoptosis induction by curcumin in the SCC25 human tongue squamous cell carcinoma cell line. Curcumin treatment of the SCC25 cells resulted in a time- and dose-dependent reduction in cell viability and cell growth, and onset of apoptotic cell death. The curcumin-treated SCC25 cells showed several types of apoptotic manifestations, such as nuclear condensation, DNA fragmentation, reduced MMP and proteasome activity, and a decreased DNA content. In addition, the treated SCC25 cells showed a release of cytochrome c into the cytosol, translocation of AIF and DFF40/CAD into the nuclei, a significant shift in the Bax/Bcl-2 ratio, and the activation of caspase-9, caspase-7, caspase-6, caspase-3, PARP, lamin A/C, and DFF45/ICAD. Furthermore, curcumin exposure resulted in a downregulation of G1 cell cycle-related proteins and upregulation of $p27^{KIP1}$. Taken together, our findings demonstrate that curcumin strongly inhibits cell proliferation by modulating the expression of G1 cell cycle-related proteins and inducing apoptosis via proteasomal, mitochondrial, and caspase cascades in SCC25 cells.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
[게시일 2004년 10월 1일]
이용약관
제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
이 이용약관은 KoreaScience 홈페이지(이하 “당 사이트”)에서 제공하는 인터넷 서비스(이하 '서비스')의 가입조건 및 이용에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.
제 2 조 (용어의 정의)
① "이용자"라 함은 당 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 당 사이트가 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을
말합니다.
② "회원"이라 함은 서비스를 이용하기 위하여 당 사이트에 개인정보를 제공하여 아이디(ID)와 비밀번호를 부여
받은 자를 말합니다.
③ "회원 아이디(ID)"라 함은 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 자신이 선정한 문자 및 숫자의 조합을
말합니다.
④ "비밀번호(패스워드)"라 함은 회원이 자신의 비밀보호를 위하여 선정한 문자 및 숫자의 조합을 말합니다.
제 3 조 (이용약관의 효력 및 변경)
① 이 약관은 당 사이트에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
② 당 사이트는 이 약관을 개정할 경우에 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 당 사이트의
초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하게 약관내용을
변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 당 사이트는 개정 전
내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.
제 4 조(약관 외 준칙)
① 이 약관은 당 사이트가 제공하는 서비스에 관한 이용안내와 함께 적용됩니다.
② 이 약관에 명시되지 아니한 사항은 관계법령의 규정이 적용됩니다.
제 2 장 이용계약의 체결
제 5 조 (이용계약의 성립 등)
① 이용계약은 이용고객이 당 사이트가 정한 약관에 「동의합니다」를 선택하고, 당 사이트가 정한
온라인신청양식을 작성하여 서비스 이용을 신청한 후, 당 사이트가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
② 제1항의 승낙은 당 사이트가 제공하는 과학기술정보검색, 맞춤정보, 서지정보 등 다른 서비스의 이용승낙을
포함합니다.
제 6 조 (회원가입)
서비스를 이용하고자 하는 고객은 당 사이트에서 정한 회원가입양식에 개인정보를 기재하여 가입을 하여야 합니다.
제 7 조 (개인정보의 보호 및 사용)
당 사이트는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원 등록정보를 포함한 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 회원 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 당 사이트의 개인정보 보호정책이 적용됩니다.
제 8 조 (이용 신청의 승낙과 제한)
① 당 사이트는 제6조의 규정에 의한 이용신청고객에 대하여 서비스 이용을 승낙합니다.
② 당 사이트는 아래사항에 해당하는 경우에 대해서 승낙하지 아니 합니다.
- 이용계약 신청서의 내용을 허위로 기재한 경우
- 기타 규정한 제반사항을 위반하며 신청하는 경우
제 9 조 (회원 ID 부여 및 변경 등)
① 당 사이트는 이용고객에 대하여 약관에 정하는 바에 따라 자신이 선정한 회원 ID를 부여합니다.
② 회원 ID는 원칙적으로 변경이 불가하며 부득이한 사유로 인하여 변경 하고자 하는 경우에는 해당 ID를
해지하고 재가입해야 합니다.
③ 기타 회원 개인정보 관리 및 변경 등에 관한 사항은 서비스별 안내에 정하는 바에 의합니다.
제 3 장 계약 당사자의 의무
제 10 조 (KISTI의 의무)
① 당 사이트는 이용고객이 희망한 서비스 제공 개시일에 특별한 사정이 없는 한 서비스를 이용할 수 있도록
하여야 합니다.
② 당 사이트는 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 구축하며 개인정보 보호정책을 공시하고 준수합니다.
③ 당 사이트는 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 객관적으로 인정될 경우에는 적절한 절차를
거쳐 즉시 처리하여야 합니다. 다만, 즉시 처리가 곤란한 경우는 회원에게 그 사유와 처리일정을 통보하여야
합니다.
제 11 조 (회원의 의무)
① 이용자는 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며,
허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 일체의 권리를 주장할 수 없습니다.
② 당 사이트가 관계법령 및 개인정보 보호정책에 의거하여 그 책임을 지는 경우를 제외하고 회원에게 부여된
ID의 비밀번호 관리소홀, 부정사용에 의하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
③ 회원은 당 사이트 및 제 3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다.
제 4 장 서비스의 이용
제 12 조 (서비스 이용 시간)
① 서비스 이용은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 운영을
원칙으로 합니다. 단, 당 사이트는 시스템 정기점검, 증설 및 교체를 위해 당 사이트가 정한 날이나 시간에
서비스를 일시 중단할 수 있으며, 예정되어 있는 작업으로 인한 서비스 일시중단은 당 사이트 홈페이지를
통해 사전에 공지합니다.
② 당 사이트는 서비스를 특정범위로 분할하여 각 범위별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만
이 경우 그 내용을 공지합니다.
제 13 조 (홈페이지 저작권)
① NDSL에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, KISTI는 복제/배포/전송권을 확보하고
있습니다.
② NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 상업적 및 기타 영리목적으로 복제/배포/전송할 경우 사전에 KISTI의 허락을
받아야 합니다.
③ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에
합치되게 인용할 수 있습니다.
④ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우
저작권법 제136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
제 14 조 (유료서비스)
① 당 사이트 및 협력기관이 정한 유료서비스(원문복사 등)는 별도로 정해진 바에 따르며, 변경사항은 시행 전에
당 사이트 홈페이지를 통하여 회원에게 공지합니다.
② 유료서비스를 이용하려는 회원은 정해진 요금체계에 따라 요금을 납부해야 합니다.
제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 15 조 (계약 해지)
회원이 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 [가입해지] 메뉴를 이용해 직접 해지해야 합니다.
제 16 조 (서비스 이용제한)
① 당 사이트는 회원이 서비스 이용내용에 있어서 본 약관 제 11조 내용을 위반하거나, 다음 각 호에 해당하는
경우 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.
- 2년 이상 서비스를 이용한 적이 없는 경우
- 기타 정상적인 서비스 운영에 방해가 될 경우
② 상기 이용제한 규정에 따라 서비스를 이용하는 회원에게 서비스 이용에 대하여 별도 공지 없이 서비스 이용의
일시정지, 이용계약 해지 할 수 있습니다.
제 17 조 (전자우편주소 수집 금지)
회원은 전자우편주소 추출기 등을 이용하여 전자우편주소를 수집 또는 제3자에게 제공할 수 없습니다.
제 6 장 손해배상 및 기타사항
제 18 조 (손해배상)
당 사이트는 무료로 제공되는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의 또는 과실로 인한 손해발생을 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
제 19 조 (관할 법원)
서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 민사 소송법상의 관할 법원에 제기합니다.
[부 칙]
1. (시행일) 이 약관은 2016년 9월 5일부터 적용되며, 종전 약관은 본 약관으로 대체되며, 개정된 약관의 적용일 이전 가입자도 개정된 약관의 적용을 받습니다.