The objective of this paper is to compare the variation of surface properties by hydrochloric acid pre-treatment and of metallic potassium and their salts loading effect for activated carbon after surfaces transformation by acid. From the results of nitrogen adsorption, each isotherm shows a distinct knee band, which is closely related to the characteristic of microporous carbons with capillary condensation in micropores. In order to present the causes of the differences in surface properties and $S_{BET}$ after the samples were treated with hydrochloric acid, pore structure and surface morphology are investigated by adsorption analysis. X-ray diffraction (XRD) patterns indicate that activated carbons show better performance for metallic potassium and potassium salts by pre-treatment with hydrochloric acid. Scanning electron microscopy (SEM) pictures of potassium/activated carbon particles provide information about the homogeneous distribution of metal or metal complex on the surface. For the chemical composition microanalysis for potassium treatment of the activated carbon pre-treated with hydrochloric acid, samples were analyzed by energy disperse X-ray (EDX). Finally, the type and quality of oxygen groups are determined from the method proposed by Boehm. A positive influence of the acidic groups on the carbon surface by acid treatment is also demonstrated by an increase in the contents of potassium salts with increasing of acidic groups calculated from Boehm titration.
Background: Inactivation of tumor suppressor genes is believed to be important in the development of many human malignancies. Recently, several lines of evidence have indicated that the wild type p53 gene located at 17p13.3, may function as a tumor suppressor gene and that a mutant p53 gene could promote transformation by inactivating normal p53 function in a dominant negative fashion. These broad spectrum of p53 mutation in human cancers provide that mutant p53 and their protein may be potential targets of tumor diagnostic and therapeutic interventions. Method: Colony formation was performed to investigate growth suppressional ability. p53 expression pattern was examined by western blot and p53-mediated transactivation ability was assessed by CAT activity. SNU C2A cells were observed in apoptotic aspects induced by etoposide and $H_2O_2$ treatment, detecting sensitivity on agent, DNA fragmentation through agarose gel, chromatin condensation by fluorescence microscope, and cell cycle distribution by FACS. Result: 1) p53 mutant his179arg ($histidine{\rightarrow}arginine$) detected in SNU C2A cells lost transcriptional activity and growth suppression ability, showing dominant negative effect on its wild type p53. 2) Etoposide-treated SNU C2A cells induced apoptosis, exhibiting dramatic reduction of cell growth, DNA fragmentation, nuclear condensation formation of apoptotic body and increment of sub-G1 cell fraction. 3) Etoposide and $H_2O_2$-treated SNU C2A cells have no high increase of p53 expression and overexpressed p53 protein changed localization, from cytoplasm to nucleus. Also, p53-mediated transcriptional activity was increased by agents-treatment. Conclusion: SNU C2A cells coexpress wild-type and mutant p53 protein induced apoptosis in the condition on DNA damage, through localizational shift from cytoplasm to nucleus of p53 protein rather than the induction of p53 protein. SNU C2A cells derived mutant p53 his179arg abrogated both the growth supression ability and transactivational activity, showing inhibition effect on transcriptional activity of wild type p53, but did not repress the activity of wild type p53 in SNU C2A cells owing to dominant activity of wild type. These cell condition may provide new gene therapeutic implications leading effective antiproliferation of cell when mutant and wild-type p53 protein were co-expressed in cell.
We investigated global gene expression from both mouse liver and mouse hepatic cell lines treated with acetaminophen (APAP) in order to compare in vivo and in vitro profiles and to assess the feasibility of the two systems. During our analyses of gene expression profiles, we picked up several down-regulated genes, such as the cytochrome P450 family 51 (Cyp51), sulfotransferase family cytosolic 1C member 2 (Sult1c2), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1 (Hmgcs1), and several genes that were up-regulated by APAP, such as growth arrest and DNA-damage-inducible 45 alpha (Gadd45a), transformation related protein 53 inducible nuclear protein 1 (Trp53inp1) and zinc finger protein 688 (Zfp688). For validation of gene function, synthesized short interfering RNAs (siRNAs) for these genes were transfected in a mouse hepatic cell line, BNL CL.2, for investigation of cell viability and mRNA expression level. We found that siRNA transfection of these genes induced down-regulation of respective mRNA expression and decreased cell viability. siRNA transfection for Cyp51 and others induced morphological alterations, such as membrane thickening and nuclear condensation. Taken together, siRNA transfection of these six genes decreased cell viability and induced alteration in cellular morphology, along with effective inhibition of respective mRNA, suggesting that these genes could be associated with APAP-induced toxicity. Furthermore, these genes may be used in the investigation of hepatotoxicity, for better understanding of its mechanism.
Nickel is the one of potent environmental, the occupational pollutants and the classified human carcinogens. It is a serious hazard to human health, when the metal exposure. To prevent human diseases from the heavy metals, it is seemingly important that understanding of how nickel exerts their toxicity and carcinogenic effect at a molecular and a genomic level. The process of nickel absorption has been demonstrated as phagocytosis, iron channel and diffusion. Uptaked nickel has been suggested to induce carcinogenesis via two pathways, a direct DNA damaging pathway and an indirect DNA damaging pathway. The former was originated from the ability of metal to generate Reactive Oxygen Species (ROS) and the reactive intermediates to interact with DNA directly. Ni-generated ROS or Nickel itself, interacts with DNAs and histones to cause DNA damage and chromosomal abnormality. The latter was originated from an indirect DNA damage via inhibition of DNA repair, or condensation and methylation of DNA. Cells have ability to protect from the genotoxic stresses by changing gene expression. Microarray analysis of the cells treated with nickel or nickel compounds, show the specific altered gene expression profile. For example, HIF-I (Hypoxia-Inducible Factor I) and p53 were well known as transcription factors, which are upregulated in response to stress and activated by both soluble and insoluble nickel compounds. The induction of these important transcription factors exert potent selective pressure and leading to cell transformation. Genes of metallothionein and family of heat shock proteins which have been known to play role in protection and damage control, were also induced by nickel treatment. These gene expressions may give us a clue to understand of the carcinogenesis mechanism of nickel. Further discussions on molecular and genomic, are need in order to understand the specific mechanism of nickel toxicity and carcinogenicity.
Transactions of the Korean hydrogen and new energy society
/
v.28
no.3
/
pp.238-245
/
2017
Mg-Ni nanoparticles were synthesized by a physical vapor condensation method (DC arc-discharge) in a mixture of argon and hydrogen atmosphere, using compressed mixture of micro powders as the raw materials. The crystal phases, morphology, and microstructures of nanoparticles were analyzed by means of X-ray diffraction (XRD) and high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM). It was found that the intermetallic compounds of $Mg_2Ni$ and $Mg_2Ni$ formed with existence of phases of Mg, Ni, and MgO in Mg-Ni nanoparticles. After one cycle of hydrogen absorption/desorption process (activation treatment), Mg-Ni nanoparticles exhibited excellent hydrogen absorption properties. $Mg_2Ni$ phase became the main phase by aphase transformation during the hydrogen treatments. The phenomenon of refinement of grain size in the nanoparticle was also observed after the hydrogen absorption/desorption processes, which was attributed to the effect of volume expansion/shrinkage and subsequent break of nanoparticles. Maximum hydrogen absorption contents are 1.75, 2.21 and 2.77 wt.% at 523, 573 and 623 K, respectively.
Water soluble organic and inorganic species are important components in atmospheric aerosol particles and may act as cloud condensation nuclei to indirectly affect the climate. To characterize organic and elemental carbon(OC and EC), water-soluble organic carbon(WSOC) and inorganic ionic species contents, daily $PM_{2.5}$ measurements were made during the wintertime at an urban site of Gwangju. Average concentrations of WSOC, $NO_3^-$, $SO_4^{2-}$ and $NH_4^+$, which are major components in the water-soluble fraction in PM2.5, are 2.11, 5.73, 3.51 and $3.31{\mu}g/m^3$, respectively, representing 12.0(2.9~23.9%), 21.0(12.9~37.6%), 11.6(2.5~25.9%) and 11.7%(3.8~18.6%) of the $PM_{2.5}$, respectively. Abundance of water soluble organic compounds ranged from 5.4 to 35.9% of total water soluble organic and inorganic components with a mean of 17.6%. Even though the sampling was performed during the winter, the average contributions of secondary OC and WSOC, as deduced from primary OC/EC(or WSOC/EC) ratio, were relatively high, accounting for 17.9%(0~44.4%) of the total OC and 11.2%(0.0~51.4%) of the total WSOC, respectively. During the sampling period, low $SO_4^{2-}/(SO_4^{2-}+SO_2$) ratio of 0.14(0.03~0.32) and relative humidity condition in the winter time suggest an possibility of impact of long-range transport and/or aqueous transformation processes such as metal catalyzed oxidation of sulfur, in-cloud processes, etc.
This research was performed to investigate the morphological changes of folliculus ovary according to the radiation dose. The whole body radiation of 200 cGy, 400 cGy, and 600 cGy was given to the each groups of 5 months-aged female mouse. Various staining methods used in this research are: Hematosylin-Eosin method, and immunohistochemistrical methods using BrdU, TUNEL, p53, p21, PCNA and inhibin. The minute structural changes of folliculus ovary were observed through an electron microscope with high magnification. The morphological changes of growing folliculus ovary became distinct as the dose of X-rays increased. Especially, the nuclei of granular cells showed manifest condensation and the changes of the transparent zone were distinct. As a result of histochemical reaction according to Masson's trichrome method and reticular fiber method, the changed granular cells, the deformed basilar membrane of folliculus ovary and the abnormal arrangement of the reticular fiber were observed. In the reaction of BrdU, the granular cells of normal folliculus ovary with positive reaction rapidly decreased according to the increase of the dose of X-rays. In TUNEL study, granular cells showing positive reaction in retarded folliculus ovary were expanded to growing folliculus ovary and primordial folliculus ovary according to the increase of the dose of X-rays. In case of 600 cGy of X-rays, oocyte underwent apoptosis. In p53 immunohistochemistry, p53 manifested to be stronger as the dose of X-rays increased. p53 reactivity was manifested distinctively in all cells comprising folliculus ovary following irradiation of 600 cGy. p21 was manifested in granular cells of folliculus ovary and showed very positive reaction around follicular antrum according to the increase of the dose of X-rays. In PCNA, positive reaction was manifested in growing folliculus ovary, mature folliculus ovary and primordial folliculus ovary, but the extent of the reaction decreased as the dose of the X-rays decreased. The finding that the reaction of granular cells around folliculus ovary was stronger than that near follicular membrane indicates that what was damaged first by X-ray was the cells near folliculus ovary and follicular antrum. The reactivity of $inhibin-{\alpha}$ showed difference according to the growing stage of folliculus ovary: $inhibin-{\alpha}$ showed the most strong reaction in mature folliculus ovary with follicular antrum. There was strong reaction in granular cells around follicular membrane but $inhibin-{\alpha}$ did not occur at all in theca cells comprising follicular membrane. $Inhibin-{\alpha}$ in ovary tissue exposed to 400 cGy of X-rays was manifested more strongly than in ovary tissue exposed to 600 cGy of X-rays, which was related to the phenomenon that granular cells of mature folliculus ovary underwent necrosis or apoptosis increasingly due to X-rays. In an electron microscope with high magnification, nuclei and protoplasm of granular cells in growing folliculus ovary abruptly underwent minute structural changes according to the increase of dose of X-rays. Cell residue, by-product of cell decease, neutrophil and macrophage around follicular antrum were observed. The minute structural changes in granular cells showed typical characteristics of apoptosis: the increase of electronic density due to nuclear condensation, fragmentation of nuclei and atrophy of protoplasm. Necrosis of cells was identified but it was not so remarkable. Macrophage with apoptotic bodies was scattered. Proportional to the radiation dose, we found that the generation of heterogeneous substance of normal ovary texture's follicular fluid, the emergence of dyeing characteristic in the basilar membrane of folicle, the generation of apoptosis, and the transformation of macrophages, etc. From this results, we can infer the possible radiation hazard on the ovary of cervix cancer patient with radiation therapy.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
[게시일 2004년 10월 1일]
이용약관
제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
이 이용약관은 KoreaScience 홈페이지(이하 “당 사이트”)에서 제공하는 인터넷 서비스(이하 '서비스')의 가입조건 및 이용에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.
제 2 조 (용어의 정의)
① "이용자"라 함은 당 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 당 사이트가 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을
말합니다.
② "회원"이라 함은 서비스를 이용하기 위하여 당 사이트에 개인정보를 제공하여 아이디(ID)와 비밀번호를 부여
받은 자를 말합니다.
③ "회원 아이디(ID)"라 함은 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 자신이 선정한 문자 및 숫자의 조합을
말합니다.
④ "비밀번호(패스워드)"라 함은 회원이 자신의 비밀보호를 위하여 선정한 문자 및 숫자의 조합을 말합니다.
제 3 조 (이용약관의 효력 및 변경)
① 이 약관은 당 사이트에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
② 당 사이트는 이 약관을 개정할 경우에 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 당 사이트의
초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하게 약관내용을
변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 당 사이트는 개정 전
내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.
제 4 조(약관 외 준칙)
① 이 약관은 당 사이트가 제공하는 서비스에 관한 이용안내와 함께 적용됩니다.
② 이 약관에 명시되지 아니한 사항은 관계법령의 규정이 적용됩니다.
제 2 장 이용계약의 체결
제 5 조 (이용계약의 성립 등)
① 이용계약은 이용고객이 당 사이트가 정한 약관에 「동의합니다」를 선택하고, 당 사이트가 정한
온라인신청양식을 작성하여 서비스 이용을 신청한 후, 당 사이트가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
② 제1항의 승낙은 당 사이트가 제공하는 과학기술정보검색, 맞춤정보, 서지정보 등 다른 서비스의 이용승낙을
포함합니다.
제 6 조 (회원가입)
서비스를 이용하고자 하는 고객은 당 사이트에서 정한 회원가입양식에 개인정보를 기재하여 가입을 하여야 합니다.
제 7 조 (개인정보의 보호 및 사용)
당 사이트는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원 등록정보를 포함한 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 회원 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 당 사이트의 개인정보 보호정책이 적용됩니다.
제 8 조 (이용 신청의 승낙과 제한)
① 당 사이트는 제6조의 규정에 의한 이용신청고객에 대하여 서비스 이용을 승낙합니다.
② 당 사이트는 아래사항에 해당하는 경우에 대해서 승낙하지 아니 합니다.
- 이용계약 신청서의 내용을 허위로 기재한 경우
- 기타 규정한 제반사항을 위반하며 신청하는 경우
제 9 조 (회원 ID 부여 및 변경 등)
① 당 사이트는 이용고객에 대하여 약관에 정하는 바에 따라 자신이 선정한 회원 ID를 부여합니다.
② 회원 ID는 원칙적으로 변경이 불가하며 부득이한 사유로 인하여 변경 하고자 하는 경우에는 해당 ID를
해지하고 재가입해야 합니다.
③ 기타 회원 개인정보 관리 및 변경 등에 관한 사항은 서비스별 안내에 정하는 바에 의합니다.
제 3 장 계약 당사자의 의무
제 10 조 (KISTI의 의무)
① 당 사이트는 이용고객이 희망한 서비스 제공 개시일에 특별한 사정이 없는 한 서비스를 이용할 수 있도록
하여야 합니다.
② 당 사이트는 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 구축하며 개인정보 보호정책을 공시하고 준수합니다.
③ 당 사이트는 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 객관적으로 인정될 경우에는 적절한 절차를
거쳐 즉시 처리하여야 합니다. 다만, 즉시 처리가 곤란한 경우는 회원에게 그 사유와 처리일정을 통보하여야
합니다.
제 11 조 (회원의 의무)
① 이용자는 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며,
허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 일체의 권리를 주장할 수 없습니다.
② 당 사이트가 관계법령 및 개인정보 보호정책에 의거하여 그 책임을 지는 경우를 제외하고 회원에게 부여된
ID의 비밀번호 관리소홀, 부정사용에 의하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
③ 회원은 당 사이트 및 제 3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다.
제 4 장 서비스의 이용
제 12 조 (서비스 이용 시간)
① 서비스 이용은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 운영을
원칙으로 합니다. 단, 당 사이트는 시스템 정기점검, 증설 및 교체를 위해 당 사이트가 정한 날이나 시간에
서비스를 일시 중단할 수 있으며, 예정되어 있는 작업으로 인한 서비스 일시중단은 당 사이트 홈페이지를
통해 사전에 공지합니다.
② 당 사이트는 서비스를 특정범위로 분할하여 각 범위별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만
이 경우 그 내용을 공지합니다.
제 13 조 (홈페이지 저작권)
① NDSL에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, KISTI는 복제/배포/전송권을 확보하고
있습니다.
② NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 상업적 및 기타 영리목적으로 복제/배포/전송할 경우 사전에 KISTI의 허락을
받아야 합니다.
③ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에
합치되게 인용할 수 있습니다.
④ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우
저작권법 제136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
제 14 조 (유료서비스)
① 당 사이트 및 협력기관이 정한 유료서비스(원문복사 등)는 별도로 정해진 바에 따르며, 변경사항은 시행 전에
당 사이트 홈페이지를 통하여 회원에게 공지합니다.
② 유료서비스를 이용하려는 회원은 정해진 요금체계에 따라 요금을 납부해야 합니다.
제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 15 조 (계약 해지)
회원이 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 [가입해지] 메뉴를 이용해 직접 해지해야 합니다.
제 16 조 (서비스 이용제한)
① 당 사이트는 회원이 서비스 이용내용에 있어서 본 약관 제 11조 내용을 위반하거나, 다음 각 호에 해당하는
경우 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.
- 2년 이상 서비스를 이용한 적이 없는 경우
- 기타 정상적인 서비스 운영에 방해가 될 경우
② 상기 이용제한 규정에 따라 서비스를 이용하는 회원에게 서비스 이용에 대하여 별도 공지 없이 서비스 이용의
일시정지, 이용계약 해지 할 수 있습니다.
제 17 조 (전자우편주소 수집 금지)
회원은 전자우편주소 추출기 등을 이용하여 전자우편주소를 수집 또는 제3자에게 제공할 수 없습니다.
제 6 장 손해배상 및 기타사항
제 18 조 (손해배상)
당 사이트는 무료로 제공되는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의 또는 과실로 인한 손해발생을 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
제 19 조 (관할 법원)
서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 민사 소송법상의 관할 법원에 제기합니다.
[부 칙]
1. (시행일) 이 약관은 2016년 9월 5일부터 적용되며, 종전 약관은 본 약관으로 대체되며, 개정된 약관의 적용일 이전 가입자도 개정된 약관의 적용을 받습니다.