We investigated whether IFN-${\beta}$ inhibits the growth of human malignant glioma and induces glioma cell apoptosis using the human IFN-${\beta}$ gene transfected into glioma cells. A eukaryonic expression vector ($pSV2IFN{\beta}$) for IFN-${\beta}$ was transfected into the glioma cell line SHG44 using liposome transfection. Stable transfection and IFN-${\beta}$ expression were confirmed using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Cell apoptosis was also assessed by Hoechst staining and electron microscopy. In vivo experiments were used to establish a SHG44 glioma model in nude mice. Liposomes containing the human IFN-${\beta}$ gene were injected into the SHG44 glioma of nude mice to observe glioma growth and calculate tumor size. Fas expression was evaluated using immunohistochemistry. The IFN-${\beta}$ gene was successfully transfected and expressed in the SHG44 glioma cells in vitro. A significant difference in the number of apoptotic cells was observed between transfected and non-transfected cells. Glioma growth in nude mice was inhibited in vivo, with significant induction of apoptosis. Fas expression was also elevated. The IFN-${\beta}$ gene induces apoptosis in glioma cells, possibly through upregulation of Fas. The IFN-${\beta}$ gene modulation in the Fas pathway and apoptosis in glioma cells may be important for the treatment of gliomas.
Brefeldin A (BFA)는 Eupenicillium brefeldianum에서 분리한 lactone계열의 항생제이며 ER에서 Golgi로 단백질 이송/전달을 억제히는 기능이 있다. 따라서 BFA를 세포에 처리 시 Golgi 기능 장애와 ER에서 단백질의 폴딩/조립의 문제로 인하여 ER에 기능 장애가 발생하는데 이를 소포체 스트레스(ER stress)라고 한다. 본 연구에서는 정상 astrocyte 세포와 C6 glioma 세포에서의 BFA처리에 따라 ER stress marker 단백질인 CHOP 발현 차이를 확인하였다. BFA 처리 시 CHOP 발현이 정상 astrocyte 세포에서 C6 glioma 세포에 비해 현저히 낮은 발현을 확인하였다. 하지만 CHOP mRNA 발현에서는 astrocyte 세포에서 발현 됨을 RT-PCR로 확인하였다. C6 glioma 세포와 비교하여 astrocyte 세포에서 BFA유도의 CHOP 단백질 발현이 낮은 원인은 proteasome 활성이 높음으로 기인됨을 proteasome inhibitor 실험과 proteasome 활성 측정을 통하여 확인하였다.
Recently, we reported that immunostimulation of primary rat cortical astrocyte caused stimulation of glucose deprivation induced apoptotic cell death. To enhance the understanding of the mechanism of the potentiated cell death of clucose-deprived astrocyte by immunostimulation, we investigated the effect of immunostimulation on the glucose deprivation induced cell death of rat C6 glioma cells. Co-treatment of C6 glioma cells with lipopolysaccharide (LPS, $1\;{\mu}\textrm{g}/ml$) and interferon ${\gamma}(IFN{\gamma},\;100U/ml)$ is serum free condition caused marked elevationo f nitric oxide production ($>50\;{\mu}M$). In this condition, glucose deprivation caused significant release of lactate dehdrogenase (LDH) from C6 glioma cells while control cells did not show LDH release. To investigate whether elevated level of nitric oxide is responsible for the enhanced LDH release in glucose-deprived condition, C6 glioma cells were treated with 3-morphorinosydnonimine (SIN-1) and it was observed that SIN-1 caused increase in LDH release from glucose-deprived C6 glioma cells. Treatment of C6 glioma cells with $25\;{\mu}M$ of pyrrolidinedithiocarbamate (PDTC) which inhibit Nuclear factor kB (NF-kB) activation, caused complete inhibition of nitric oxide production. Treatment of C6 glioma cells with NO synthase inhibitors, $N^{G}$-nitro-L-arginine (NNA) or L-$N{\omega}$-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME), caused inhibition of nitric oxide production and also glucose deprivation induced cell death of cytokine-stimulated C6 glioma cells. In addition, diaminohydroxypyrimidine (DAHP, 5 mM) which inhibits the synthesis of tetrahydrobiopterine (BH4), one of essential cofactors for iNOS activity, caused complete inhibition of NO production from immunostimulated C6 glioma cells. The results from the present study suggest that immunostimulation causes potentiation of glucose deprivation induced death of C6 glioma cells which is mediated at least in part by the increased production of nitric oxide. The vulnerability of immunostimulated C6 glioma cells to hypoglycemic insults may implicate that the elevated level of cytokines in various ischemic and neurodegenerative diseases may play a role in their pathogenesis.
Toxic effect of Hexavalent chromium $(CrO_3)$ on various cells and organs has been well recognized. However, the mechanism and degree of cytotoxicity of $CrO_3$ remain unclear. This study was performed to examine the cytotoxicity of $CrO_3$ on $C_6$ glioma cells by measuring cell viability. The XTT assay, one of the sensitive methods to determine the cell viability, was taken to examine the viability of glioma cells treated with $CrO_3$. In this study, not only decreased the number of glioma cells but morphologic changes of them were noted and cell viability decreased in a time and dose-dependent manner after treated with various concentrations of $CrO_3$ for 48hours. $IC_{90}\;and\;IC_{50}$ values in XTT assay were determined at $25{\mu}M\;and\;55{\mu}M$$CrO_3$, respectively. These results suggest that Hexavalent chromium has a highly cytotoxic effect and has a time and dose-dependent cytotoxicity on $C_6$ glioma cells.
Human glioma, arising from glial cells of the central nervous system, accounts for almost 30%of all brain tumours, neoplasms with a poor prognosis and high mortality rates worldwide. In the present study we assessed tissue architectural modifications associated with macrophage lineage cells, controversial major immune effector cells within the brain, in human glioma tissue samples from eastern India. Ethically cleared post-operative human glioma samples from our collaborative neurosurgery unit with respective CT/MRI and patient history were collected from the Nodal Centre of Neurosciences in Kolkata, over 9 months. Along with conventional histopathology, samples were subjected to silver-gold staining and fluorescence tagged immunophenotyping for the detection of electron dense brain macrophage/microglia cells in glioma tissue, followed by immune-phenotyping of cells. With higher grades, CD11b+/Iba-1+ macrophage/microglia architecture with de-structured boundaries of glioma lesions indicated malfunction and invasive effector state. Present study documented a contribution of microglia to glioma progression in Eastern India.
The aim of this study was to investigate the effects of olanzapine on growth inhibition as well as autophagy in glioma cells in vitro and in vivo. The proliferation of both LN229 and T98 glioma cells, measured by MTT assay, was suppressed in a concentration-dependent and time-dependent manner. Moreover, apoptosis of both cells was significantly increased with the treatment of olanzapine as evidenced by increased Bcl-2 expression, Hoechst 33258 staining and annexinV-FITC/PI staining. Olanzapine treatment also enhanced activation of autophagy with increased expression of LC3-II, expression of protein p62, a substrate of autophagy, being decreased. The growth inhibition by olanzapine in both glioma cell lines could be blocked by co-treatment with 3-MA, an autophagy inhibitor. Furthermore, olanzapine effectively blocked the growth of subcutaneous xenografts of LN229 glioma cells in vivo. The increased level of protein LC3-II and decreased level of p62 followed by a decreased level of Bcl-2, suggesting that autophagy may contribute to apoptosis. In addition, reduced proliferation of glioma cells was shown by a decrease of Ki-67 staining and increased caspase-3 staining indicative of apoptosis in mouse xenografts. These results indicated that olanzapine inhibited the growth of glioma cells accompanied by induction of autophagy and apoptosis both in vitro and in vivo. Olanzapine-induced autophagy plays a tumor-suppressing role in glioma cells.
Growing evidence shows that deregulation of the circadian clock plays an important role in the development of malignant tumors, including gliomas. However, the molecular mechanisms of gene chnages controlling circadian rhythm in glioma cells have not been explored. Using real time polymerase chain reaction and immunohistochemistry techniques, we examined the expression of two important clock genes, cry1 and cry2, in 69 gliomas. In this study, out of 69 gliomas, 38 were cry1-positive, and 51 were cry2-positive. The expression levels of cry1 and cry2 in glioma cells were significantly different from the surrounding non-glioma cells (P<0.01). The difference in the expression rate of cry1 and cry 2 in high-grade (grade III and IV) and low-grade (grade 1 and II) gliomas was non-significant (P>0.05) but there was a difference in the intensity of immunoactivity for cry 2 between high-grade gliomas and low-grade gliomas (r=-0.384, P=0.021). In this study, we found that the expression of cry1 and cry2 in glioma cells was much lower than in the surrounding non-glioma cells. Therefore, we suggest that disturbances in cry1 and cry2 expression may result in the disruption of the control of normal circadian rhythm, thus benefiting the survival of glioma cells. Differential expression of circadian clock genes in glioma and non-glioma cells may provide a molecular basis for the chemotherapy of gliomas.
Objective: Currently available therapies for human malignant gliomas have limited efficacy. Toxoplasma gondii, an obligate intracellular protozoan parasite, and Quil-A are nonspecific, potent immune stimulants. T. gondii is shown to have antitumor activity in some types of cancers. Therefore, this study is undertaken to evaluate the antitumor effect of Toxoplasma lysate antigen (TLA), alone or in combination with Quil-A, on human glioma U373MG and U87MG cells. Methods: The in vitro effects of TLA alone or in combination with Quil-A on the proliferation, invasion, and apoptosis of glioma cells were tested using MTT, Matrigel invasion, and DNA fragmentation assays, and the in vivo effects on the growth of gliomas were evaluated in athymic nude mice transplanted with glioma cells. Results: Treatment with TLA resulted in the suppressed proliferation and invasion of both U373MG and U87MG cells, in a dose-dependent manner. In addition, at high concentration, TLA induced glioma cell apoptosis. When TLA was administered in the mouse glioma model, malignant glioma growth was decreased. The combined treatment of TLA with Quil-A significantly inhibited the proliferation and invasion of cultured cells as well as tumor mass of implanted mice. Conclusion: TLA inhibits the proliferation and invasion of glioma cells in vitro and in vivo, and these antitumor effects of TLA are significantly enhanced by the addition of Quil-A.
Lee, Kang Pa;Choi, Nan Hee;Kim, Jin Teak;Park, In-Sik
Nutrition Research and Practice
/
제9권3호
/
pp.256-261
/
2015
BACKGROUND/OBJECTIVES: Yacon (Samallanthus sonchifolius), a common edible plant grown throughout the world, is well known for its antidiabetic properties. It is also known to have several other pharmacological properties including anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-allergic, and anti-cancer effects. To date, the effect of yacon on gliomas has not been studied. In this study, we investigated the effects of yacon on the migration and proliferation of C6 glioma cells stimulated by fetal bovine serum (FBS). MATERIALS/METHODS: Cell growth and proliferation were determined by evaluating cell viability using an EZ-Cytox Cell Viability Assay Kit. FBS-induced migration of C6 glioma cells was evaluated by performing the scratch wound healing assay and the Boyden chamber assay. We also used western blot analysis to determine the expression levels of extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2), a major regulator of migration and proliferation of glioma cells. Matrix metallopeptidase (MMP) 9 and TIMP-1 levels were measured by performing reverse transcription PCR. RESULTS: Yacon ($300{\mu}g/mL$) reduced both the FBS-induced proliferation of C6 glioma cells and the dose-dependent migration of the FBS-stimulated C6 cells. FBS-stimulated C6 glioma cells treated with yacon (200 and $300{\mu}g/mL$) showed reduced phosphorylation of ERK1/2 and inhibition of MMP 9 expression compared to those shown by the untreated FBS-stimulated C6 cells. In contrast, yacon (200 and $300{\mu}g/mL$) induced TIMP-1 expression. CONCLUSIONS: On the basis of these results, we suggest that yacon may exert an anti-cancer effect on FBS-stimulated C6 glioma cells by inhibiting their proliferation and migration. The most likely mechanism for this is down-regulation of ERK1/2 and MMP9 and up-regulation of TIMP-1 expression levels.
It is demonstrated that inorganic mercury has cytotoxic effect on glial cells. Recently, oxygen radicals is involved in methylmercuric chloride (MMC)-induced cytotoxicity. But, the toxic mechanism of MMC is left unknown. The purpose of this study was to examine the cytotoxicity of MMC on $C_6$ glioma cells. The cytotoxicy was measured by cell viability using XTT assay in $C_6$ glioma cells. Colorimetric assay is regarded as a very sensitive screening method for the determination of the cell viability on various agents. In this study, MMC decreased cell viability according to the dose- and time dependent manners after $C_6$ glioma cells were grown with various concentrations of MMC for 48 hours. In the protective effect of allopurinol on MMC-induced cytotoxicity, allopurinol was effective in the prevention of MMC-induced cytotoxicity in these cultures. These results suggest that MMC has highly cytotoxic effect on $C_6$ glioma cells by the decrease of cell viavility, and free radical scavenger such as allopurinol was effective on organic mercury-induced cytotoxicity in these cultures.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
[게시일 2004년 10월 1일]
이용약관
제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
이 이용약관은 KoreaScience 홈페이지(이하 “당 사이트”)에서 제공하는 인터넷 서비스(이하 '서비스')의 가입조건 및 이용에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.
제 2 조 (용어의 정의)
① "이용자"라 함은 당 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 당 사이트가 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을
말합니다.
② "회원"이라 함은 서비스를 이용하기 위하여 당 사이트에 개인정보를 제공하여 아이디(ID)와 비밀번호를 부여
받은 자를 말합니다.
③ "회원 아이디(ID)"라 함은 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 자신이 선정한 문자 및 숫자의 조합을
말합니다.
④ "비밀번호(패스워드)"라 함은 회원이 자신의 비밀보호를 위하여 선정한 문자 및 숫자의 조합을 말합니다.
제 3 조 (이용약관의 효력 및 변경)
① 이 약관은 당 사이트에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
② 당 사이트는 이 약관을 개정할 경우에 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 당 사이트의
초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하게 약관내용을
변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 당 사이트는 개정 전
내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.
제 4 조(약관 외 준칙)
① 이 약관은 당 사이트가 제공하는 서비스에 관한 이용안내와 함께 적용됩니다.
② 이 약관에 명시되지 아니한 사항은 관계법령의 규정이 적용됩니다.
제 2 장 이용계약의 체결
제 5 조 (이용계약의 성립 등)
① 이용계약은 이용고객이 당 사이트가 정한 약관에 「동의합니다」를 선택하고, 당 사이트가 정한
온라인신청양식을 작성하여 서비스 이용을 신청한 후, 당 사이트가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
② 제1항의 승낙은 당 사이트가 제공하는 과학기술정보검색, 맞춤정보, 서지정보 등 다른 서비스의 이용승낙을
포함합니다.
제 6 조 (회원가입)
서비스를 이용하고자 하는 고객은 당 사이트에서 정한 회원가입양식에 개인정보를 기재하여 가입을 하여야 합니다.
제 7 조 (개인정보의 보호 및 사용)
당 사이트는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원 등록정보를 포함한 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 회원 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 당 사이트의 개인정보 보호정책이 적용됩니다.
제 8 조 (이용 신청의 승낙과 제한)
① 당 사이트는 제6조의 규정에 의한 이용신청고객에 대하여 서비스 이용을 승낙합니다.
② 당 사이트는 아래사항에 해당하는 경우에 대해서 승낙하지 아니 합니다.
- 이용계약 신청서의 내용을 허위로 기재한 경우
- 기타 규정한 제반사항을 위반하며 신청하는 경우
제 9 조 (회원 ID 부여 및 변경 등)
① 당 사이트는 이용고객에 대하여 약관에 정하는 바에 따라 자신이 선정한 회원 ID를 부여합니다.
② 회원 ID는 원칙적으로 변경이 불가하며 부득이한 사유로 인하여 변경 하고자 하는 경우에는 해당 ID를
해지하고 재가입해야 합니다.
③ 기타 회원 개인정보 관리 및 변경 등에 관한 사항은 서비스별 안내에 정하는 바에 의합니다.
제 3 장 계약 당사자의 의무
제 10 조 (KISTI의 의무)
① 당 사이트는 이용고객이 희망한 서비스 제공 개시일에 특별한 사정이 없는 한 서비스를 이용할 수 있도록
하여야 합니다.
② 당 사이트는 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 구축하며 개인정보 보호정책을 공시하고 준수합니다.
③ 당 사이트는 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 객관적으로 인정될 경우에는 적절한 절차를
거쳐 즉시 처리하여야 합니다. 다만, 즉시 처리가 곤란한 경우는 회원에게 그 사유와 처리일정을 통보하여야
합니다.
제 11 조 (회원의 의무)
① 이용자는 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며,
허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 일체의 권리를 주장할 수 없습니다.
② 당 사이트가 관계법령 및 개인정보 보호정책에 의거하여 그 책임을 지는 경우를 제외하고 회원에게 부여된
ID의 비밀번호 관리소홀, 부정사용에 의하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
③ 회원은 당 사이트 및 제 3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다.
제 4 장 서비스의 이용
제 12 조 (서비스 이용 시간)
① 서비스 이용은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 운영을
원칙으로 합니다. 단, 당 사이트는 시스템 정기점검, 증설 및 교체를 위해 당 사이트가 정한 날이나 시간에
서비스를 일시 중단할 수 있으며, 예정되어 있는 작업으로 인한 서비스 일시중단은 당 사이트 홈페이지를
통해 사전에 공지합니다.
② 당 사이트는 서비스를 특정범위로 분할하여 각 범위별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만
이 경우 그 내용을 공지합니다.
제 13 조 (홈페이지 저작권)
① NDSL에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, KISTI는 복제/배포/전송권을 확보하고
있습니다.
② NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 상업적 및 기타 영리목적으로 복제/배포/전송할 경우 사전에 KISTI의 허락을
받아야 합니다.
③ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에
합치되게 인용할 수 있습니다.
④ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우
저작권법 제136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
제 14 조 (유료서비스)
① 당 사이트 및 협력기관이 정한 유료서비스(원문복사 등)는 별도로 정해진 바에 따르며, 변경사항은 시행 전에
당 사이트 홈페이지를 통하여 회원에게 공지합니다.
② 유료서비스를 이용하려는 회원은 정해진 요금체계에 따라 요금을 납부해야 합니다.
제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 15 조 (계약 해지)
회원이 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 [가입해지] 메뉴를 이용해 직접 해지해야 합니다.
제 16 조 (서비스 이용제한)
① 당 사이트는 회원이 서비스 이용내용에 있어서 본 약관 제 11조 내용을 위반하거나, 다음 각 호에 해당하는
경우 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.
- 2년 이상 서비스를 이용한 적이 없는 경우
- 기타 정상적인 서비스 운영에 방해가 될 경우
② 상기 이용제한 규정에 따라 서비스를 이용하는 회원에게 서비스 이용에 대하여 별도 공지 없이 서비스 이용의
일시정지, 이용계약 해지 할 수 있습니다.
제 17 조 (전자우편주소 수집 금지)
회원은 전자우편주소 추출기 등을 이용하여 전자우편주소를 수집 또는 제3자에게 제공할 수 없습니다.
제 6 장 손해배상 및 기타사항
제 18 조 (손해배상)
당 사이트는 무료로 제공되는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의 또는 과실로 인한 손해발생을 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
제 19 조 (관할 법원)
서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 민사 소송법상의 관할 법원에 제기합니다.
[부 칙]
1. (시행일) 이 약관은 2016년 9월 5일부터 적용되며, 종전 약관은 본 약관으로 대체되며, 개정된 약관의 적용일 이전 가입자도 개정된 약관의 적용을 받습니다.